Box 1
Container
Contains 271 Results:
West Hartford, Connecticut, 1933-1946
Item — Box: 1
Identifier: I.A
West Avon, Connecticut, 1933-1946
Item — Box: 1
Identifier: I.A
West Cornwall, Connecticut, 1934-1942
Item — Box: 1
Identifier: I.A
West Willington, Connecticut, 1940-04-03
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Wolcott Hill, Connecticut, 1931-1932
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Lone Pine, California, 1916-02-02
Item — Box: 1
Identifier: I.E
Long Beach, California, 1938-01-27
Item — Box: 1
Identifier: I.E
Los Angeles, California, 1936-1939
Item — Box: 1
Identifier: I.E
Los Gatos, California, 1930-1943
Item — Box: 1
Identifier: I.E
Marysville, California, 1938-01-25
Item — Box: 1
Identifier: I.E