Box 1
Container
Contains 271 Results:
Darien, Connecticut, 1905-04-20
Item — Box: 1
Identifier: I.A
East Haven, Connecticut, 1933-1944
Item — Box: 1
Identifier: I.A
East Lyme, Connecticut, 1937-1946
Item — Box: 1
Identifier: I.A
East Norwalk, Connecticut, 1937-10-03
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Fairfield, Connecticut, 1905-04-23
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Farmington, Connecticut, 1939-1944
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Glastonbury, Connecticut, 1907-1944
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Green Farms, Connecticut, 1927-1948
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Greenwich, Connecticut, 1926-1948
Item — Box: 1
Identifier: I.A
Haddam, Connecticut, 1936-1944
Item — Box: 1
Identifier: I.A